-
-
Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen - Bahnstraße 32, 2130, Mistelbach, AUT, Austria
Company Information
- Company registration number
- 55259p
- Company Status
- LIVE
- Country
- Austria
- Registered Address
- Bahnstraße 32
- 2130
- Mistelbach
- AUT Bahnstraße 32, 2130, Mistelbach, AUT AT
Management
- Managing Directors
-
Johannes Stöger (VORSTAND)
Wildendürnbach 264, 2164, Wildendürnbach, AUT -
Ing. Herbert Bartosch (VORSTAND)
Hauptstraße 47, 2273, Hohenau/March, AUT -
Werner Girsch (VORSTAND)
Kaiser-Franz-Josef Straße 92, 2144, Altlichtenwarth, AUT -
Ing. Gerhard Poiss (VORSTAND)
Hauptstraße 68, 2182, Palterndorf, AUT -
Josef Klampfl jun. (VORSTAND)
Olgersdorf 65, 2151, Olgersdorf, AUT -
Ing. Adolf Mechtler (VORSTAND)
Hauptstraße 85, 2123, Wolfpassing, AUT -
Karl Pleil (VORSTAND)
Hüttendorf 68, 2130, Hüttendorf, AUT -
Andreas Kraft (VORSTAND)
Unterstinkenbrunn 7, 2154, Unterstinkenbrunn, AUT -
Günter Leisser (VORSTAND)
Pottenhofen 61, 2163, Pottenhofen, AUT -
Gerhard Strasser (VORSTAND)
Wienerstraße 38, 2193, Hobersdorf, AUT -
Franz Flandorfer (VORSTAND)
Raiffeisengasse 18, 2191, Höbersbrunn, AUT -
Martin Ostermayer (VORSTAND)
Marktplatz 6, 2136, Laa an der Thaya, AUT -
Ing. Wolfgang Hackl (VORSTAND)
Dorfstraße 20, 2191, Atzelsdorf, AUT -
Ing. Pavel Stejskal (VORSTAND)
Ponetovice 5, 66451, Ponetovice, CZE -
Richard Schober (VORSTAND)
Wienerstraße 11, 2191, Gaweinstal, AUT -
Josef Steininger (VORSTAND)
Kettlasbrunner Hauptstraße 42, 2192, Kettlasbrunn, AUT -
Karl Draxler (VORSTAND)
Unterort 86, 2130, Eibesthal, AUT -
Gertraud Kastner (VORSTAND)
Meierhof 1, 2134, Staatz-Kautendorf, AUT -
Andreas Bruckner (VORSTAND)
Wulzeshofen 14, 2064, Wulzeshofen, AUT -
Josef Friedl (VORSTAND)
Zwingendorf 37, 2063, Zwingendorf, AUT -
Ing. Martin Schulz (VORSTAND)
Zwentendorf 14, 2152, Zwentendorf, AUT -
Leopold Strobl (VORSTAND)
Obere Hauptstraße 21, 2222, Bad Pirawarth, AUT -
Stefan Uhl (VORSTAND)
Fallbach 58, 2133, Fallbach, AUT -
Markus Schild (VORSTAND)
Hagenberg 53, 2133, Hagenberg, AUT -
Johannes Hess (VORSTAND)
Milchhausstrasse 35, 2223, Hohenruppersdorf, AUT -
Volkmar Kober (VORSTAND)
Nr. 55, 2134, Wultendorf, AUT -
Johann Kölbl (VORSTAND)
Nr. 116, 2136, Hanfthal, AUT -
Josef Weiss (VORSTAND)
Mühlbachweg 250, 2276, Katzelsdorf, AUT -
Günter Binder (VORSTAND)
Hauptstraße 6, 2262, Stillfried, AUT -
Ludwig Graf (VORSTAND)
Lundenburgerstraße 25, 2143, Großkrut, AUT -
Erich Andre (VORSTAND)
Nr. 68, 2225, Windisch Baumgarten, AUT -
Johann Bauer (VORSTAND)
Gr. Zeile 13, 2172, Schrattenberg, AUT -
Roman Bayer (VORSTAND)
Wieden 72, 2162, Falkenstein, AUT -
Werner Bayler (VORSTAND)
Gasse 28, 2276, Reintal, AUT -
Wolfgang Dollinger (VORSTAND)
Winterseite 8, 2225, Loidesthal, AUT -
Alfred Ertl (VORSTAND)
Hauptstraße 108, 2275, Bernhardsthal, AUT -
Christian Fehlmann (VORSTAND)
Hauptstraße 15, 2165, Drasenhofen, AUT -
Heinz Heger (VORSTAND)
Wilhelmsdorfer Straße 4, 2170, Poysdorf, AUT -
Martin Hirtl (VORSTAND)
Brunngasse 72, 2170, Poysdorf, AUT -
Gerald Huber (VORSTAND)
Lundenburgerstraße 23, 2143, Großkrut, AUT -
Anita Schwalm (VORSTAND)
Große Zeile 30, 2171, Herrnbaumgarten, AUT -
Erich Köcher (VORSTAND)
Poysdorfer Straße 60, 2143, Großkrut, AUT -
Dr.DI. Andreas Leidwein (VORSTAND)
Hauptstraße 5, 2263, Dürnkrut, AUT -
Andreas Redl (VORSTAND)
Gaiselberg 26, 2225, Zistersdorf, AUT -
Herbert Pech (VORSTAND)
Obere Hauptstraße 26, 2165, Stützenhofen, AUT -
Karl Bogensdorfer (VORSTAND)
Nr. 77, 2224, Niedersulz, AUT -
DI Markus Schodl-Klamm (VORSTAND)
Feldsbergerstraße 31, 2170, Poysdorf, AUT -
Ing. Werner Schuller (VORSTAND)
Nr. 290, 2225, Groß Inzersdorf, AUT -
Christiana Schulz (VORSTAND)
Nr. 23, 2143, Ginzersdorf, AUT -
Johann Schweighofer (VORSTAND)
Alte Marktstraße 9, 2225, Zistersdorf, AUT -
DI Christina Spangl (VORSTAND)
Reintal 2, 2276, Reintal, AUT -
Rainer Weiss (VORSTAND)
Hauptstraße 58, 2276, Katzelsdorf, AUT -
Alfred Wachter (VORSTAND)
Nr. 353, 2153, Stronsdorf, AUT -
Karl Feilhammer (VORSTAND)
Hauptstraße 21, 2126, Ladendorf, AUT -
Regina Geyer (VORSTAND)
Ringstraße 57, 2193, Bullendorf, AUT -
Günter Ehm (VORSTAND)
Hauptstraße 25, 2263, Waidendorf, AUT -
Roman Kraft (VORSTAND)
Schulgasse 38, 2124, Oberkreuzstetten, AUT -
Clemens Manhart (VORSTAND)
Laaer Straße 27, 2135, Neudorf im Weinviertel, AUT -
Stefan Scheiner (VORSTAND)
Obere Laaerstraße 15, 2132, Hörersdorf, AUT -
Gerald Kridlo (VORSTAND)
Maria Bründl 10, 2264, Sierndorf/March, AUT
- Company secretaries
-
Ing. Alfred Hiller (PROKURIST/IN)
Berggasse 7, 2122, Riedenthal, AUT -
Reinhard Thürr (PROKURIST/IN)
Immendorf 232, 2022, Immendorf, AUT
- Officers
-
RAIFFEISEN-REVISIONSVERBAND (REVISIONSVERBAND)
Hammer-Purgstall-Gasse 6, 1020, Wien, AUT
Company Details
- Type of Business
- Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
- Incorporated
- 1920-04-15
- Age Of Company 1920-04-15 105 years
Ownership
- Share Capital
- 50 EUR
Jurisdiction Particularities
- Court
- Landesgericht Korneuburg
- Previous Names
- Raiffeisen-Lagerhaus Laa a.d. Thaya registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 5299001KJYVOHEIY9325
- Identnumber
- 36056
- Phone
- 02572 27 15-0
-
Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen Company Description
- 02572 27 15-0 .
Get Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870
You are here: Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost Egen - Bahnstraße 32, 2130, Mistelbach, AUT, Austria
- 1920-04-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Firmenbuch
- 2023-09-14 Modification
- Für die Firma mit der offiziellen Registernummer *p wurde ein neuer Jahresabschluss eingetragen und wurde eine neuer Konzernabschluss eingereicht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Änderung am *-*-* eingetragen.
-
Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen
Did you know? kompany provides original and official company documents for Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost eGen as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Annual Accounts
Financial data for the last reported full year
Articles of Association
Founding documents
Credit Report by KSV1870
Official credit data
Credit Check by KSV1870
Brief credit details
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2023
-
2023-08-29 - Ergänzungsantrag
-
2023-08-01 - Liste
-
2023-05-24 - Einladung
keyboard_arrow_right 2022
-
2022-10-20 - Musterzeichnung
-
2022-10-20 - Antrag
-
2022-07-25 - Musterzeichnung
-
2022-08-10 - Antrag
-
2022-07-26 - Musterzeichnung
-
2022-06-21 - Einladung
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-12-09 - Protokoll
-
2021-09-28 - Protokoll
-
2021-09-03 - Einladung
-
2021-10-10 - Antrag
-
2021-06-18 - Musterzeichnung
-
2021-05-19 - Protokoll
-
2021-06-21 - Antrag
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-10-05 - Antrag
-
2020-09-25 - Antrag
-
2020-09-29 - Ergänzungsantrag
-
2020-09-29 - Bestätigung
-
2020-08-20 - Musterzeichnung
-
2020-08-19 - Sonstiges Dokument
-
2020-08-03 - Einladung
-
2020-09-04 - Mitteilung
-
2020-09-04 - Zeichnungsbestätigung
-
2020-09-03 - Zeichnungsbestätigung
-
2020-08-31 - Zeichnungsbestätigung
-
2020-09-07 - Zeichnungsbestätigung
-
2020-08-20 - Zeichnungsbestätigung
-
2020-08-19 - Verschmelzungsvertrag
-
2020-09-01 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2020-09-02 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2020-09-11 - Antrag
-
2020-06-19 - Ergänzungsantrag
-
2020-06-12 - Ergänzungsantrag
-
2020-05-29 - Kaufvertrag
-
2020-05-29 - Antrag
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-12-31 - Verschmelzungsbilanz
-
2019-07-01 - Liste
-
2019-06-26 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2019-07-10 - Antrag
-
2019-02-26 - Liste
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-09-05 - Musterzeichnung
-
2018-08-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2018-09-07 - Antrag
-
2018-09-03 - Liste
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-06-20 - Liste
-
2017-06-21 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2017-07-14 - Antrag
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-07-19 - Musterzeichnung
-
2016-07-04 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2016-07-04 - Liste
-
2016-07-25 - Antrag
-
2016-06-23 - Musterzeichnung
-
2016-07-01 - Antrag
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-06-09 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2015-06-18 - Antrag
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-09-16 - Musterzeichnung
-
2014-09-16 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
-
2014-09-16 - Liste
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-06-17 - Liste
-
2013-06-17 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2013-07-22 - Antrag
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-06-18 - Musterzeichnung
-
2012-06-18 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
-
2012-06-25 - Antrag
-
2012-06-18 - Liste
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2011-06-28 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2011-06-28 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-06-28 - Musterzeichnung
-
2010-06-28 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2010-06-28 - Liste
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-12-31 - Lagebericht
-
2008-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2008-06-30 - Protokoll d. Delegiertenversammlung
-
2008-07-14 - Musterzeichnung
-
2008-07-07 - Liste
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2007-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2007-12-31 - Lagebericht
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-12-31 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2006-12-31 - Lagebericht
-
2006-12-31 - Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss
-
2006-06-07 - Protokoll
-
2006-09-14 - Musterzeichnung
keyboard_arrow_right 2005
-
2005-07-06 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2005-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2005-12-31 - Lagebericht