-
-
Aurea Software GmbH in Liqu. - p.A. WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH &, Co KG, Schubertring 6, 1010, Wien, Austria
Company Information
- Company registration number
- 113675w
- Company Status
- CLOSED
- Country
- Austria
- Registered Address
- p.A. WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH &
- Co KG, Schubertring 6
- 1010
- Wien
- AUT p.A. WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH &, Co KG, Schubertring 6, 1010, Wien, AUT AT
Management
- Managing Directors
-
Andrew Price (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Aurea Software GmbH, p.A. WOLF THEISS, 1010, Wien, AUT -
Mag. Gernot Rauter (GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich))
Hegelgasse 13, 1010, Wien, AUT
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 1988-04-29
- Activity
- Software-Entwicklung und Marketing
Ownership
- Shareholders
- Aurea Software FZ-LLC (GESELLSCHAFTER/IN, 11333240 EUR, 97.96%) 706, Al Thuraya Tower-1 P.O. Box 502091 Media City, Dubai ARE
- Aurea Software GmbH - gemäß § 159Abs 2 Z 3 AktG, iVm § 81 GmbHG (GESELLSCHAFTER/IN, 235649 EUR, 2.04%)
- Liquidator
- Mag. Gernot Rauter
- Share Capital
- 11568889 EUR
- Paidup Capital
- 11568889
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- gelöscht
- -
- -
- Court
- Handelsgericht Wien
- Previous Names
- Update Marketing Service Gesellschaft m.b.H.
- Identnumber
- 656704
- Phone
- 01 878 55-0
-
Aurea Software GmbH in Liqu. Company Description
- 01 878 55-0 .
Get Aurea Software GmbH in Liqu. Register ReportAnnual AccountsArticles of AssociationCredit Report by KSV1870Credit Check by KSV1870
You are here: Aurea Software Gmbh In Liqu. - p.A. WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH &, Co KG, Schubertring 6, 1010, Wien, Austria
-
Announcements from the Firmenbuch
- 2023-03-09 Striking off
- Die Firma mit der offiziellen Registernummer *w wurde aus dem Firmenbuch gelöscht. Diese Bekanntmachung wurde im Firmenbuch mit der Vollzugsnummer * und Typ Löschung am *-*-* eingetragen.
-
Aurea Software GmbH in Liqu.
Did you know? kompany provides original and official company documents for Aurea Software GmbH in Liqu. as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Annual Accounts
Financial data for the last reported full year
Articles of Association
Founding documents
Credit Report by KSV1870
Official credit data
Credit Check by KSV1870
Brief credit details
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2022
-
2022-04-29 - Musterzeichnung
-
2022-04-29 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2022-04-29 - Antrag
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-09-27 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2021-09-27 - Verschmelzungsvertrag
-
2021-10-06 - Antrag
-
2021-09-27 - Antrag
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-12-31 - Ergebnisverwendungsbeschluss
-
2020-06-29 - Beschluss d. Gesellschafter
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-11-01 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2019-11-25 - Musterzeichnung
-
2019-01-23 - Antrag
-
2019-01-24 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2019-01-16 - Antrag
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-06-01 - Vereinbarung
-
2016-10-31 - Antrag
-
2016-09-23 - Beschluss d. Gesellschafter
-
2016-09-23 - Musterzeichnung
-
2016-09-14 - Antrag
-
2016-06-23 - Protokoll d. Generalversammlung
-
2016-09-05 - Antrag
-
2016-07-23 - Antrag
-
2016-06-09 - Antrag
-
2016-05-31 - Antrag
-
2016-04-21 - Antrag
-
2016-05-11 - Antrag
-
2016-04-19 - Antrag
-
2016-03-15 - Antrag
-
2016-02-18 - Antrag
-
2016-02-03 - Antrag
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-05-08 - Gutachten
-
2015-10-20 - Antrag
-
2015-04-24 - Sonstiges Dokument
-
2015-09-28 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2015-07-29 - Antrag
-
2015-11-08 - Vollmacht
-
2015-11-17 - Antrag
-
2015-11-12 - Antrag
-
2015-11-04 - Vereinbarung
-
2015-06-10 - Rücktrittserklärung
-
2015-05-04 - Rücktrittserklärung
-
2015-07-13 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2015-07-21 - Antrag
-
2015-04-23 - Satzung
-
2015-04-23 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2015-04-23 - Antrag
-
2015-04-08 - Antrag
-
2015-03-26 - Antrag
-
2015-01-26 - Antrag
-
2015-01-22 - Antrag
-
2015-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2015-12-04 - Musterzeichnung
-
2015-12-14 - Antrag
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2014-10-14 - Musterzeichnung
-
2014-10-14 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2014-10-03 - Antrag
-
2014-08-27 - Musterzeichnung
-
2014-08-26 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2014-08-26 - Antrag
-
2014-08-26 - Protokoll
-
2014-09-18 - Antrag
-
2014-08-26 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2014-02-20 - Antrag
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2013-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2013-06-19 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2013-07-23 - Antrag
-
2013-04-23 - Sonstiges Dokument
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2012-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2012-06-21 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2012-06-21 - Bericht
-
2012-08-02 - Antrag
-
2012-04-20 - Sonstiges Dokument
-
2012-01-11 - Antrag
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2011-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2011-12-31 - Sonstiges Dokument
-
2011-05-18 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2011-03-10 - Sonstiges Dokument
-
2011-04-11 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2011-04-11 - Antrag
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2010-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2010-12-13 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2010-12-01 - Musterzeichnung
-
2010-11-02 - Rücktrittserklärung
-
2010-11-30 - Antrag
-
2010-05-18 - Satzung
-
2010-05-18 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2010-06-17 - Antrag
-
2010-04-13 - Bericht
-
2010-04-28 - Antrag
-
2010-04-13 - Antrag
-
2010-03-05 - Verzeichnis der Zeichner
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2009-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2009-05-26 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2009-06-23 - Satzung
-
2009-03-11 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2009-03-17 - Satzung
-
2009-03-04 - Verzeichnis der Zeichner
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-12-31 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2008-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2008-11-27 - Musterzeichnung
-
2008-06-11 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2008-07-16 - Antrag
-
2008-06-11 - Antrag
-
2008-02-01 - Satzung
-
2008-02-01 - Verzeichnis der Zeichner
-
2008-02-01 - Beschluss d. Aufsichtsrates
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-12-31 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2007-06-26 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2007-07-30 - Satzung
-
2007-04-25 - Bericht des Aufsichtsrates
-
2007-07-25 - Antrag
-
2007-06-04 - Zeichnungsschein
-
2007-06-09 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2007-05-23 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2007-05-08 - Beschluss d. Vorstandes
-
2007-06-08 - Verzeichnis der Zeichner
-
2007-02-01 - Beschluss d. Aufsichtsrates
-
2007-02-01 - Verzeichnis der Zeichner
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-09-13 - Musterzeichnung
-
2006-04-26 - Bericht
-
2006-06-22 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2006-02-03 - Beschluss d. Aufsichtsrates
keyboard_arrow_right 2005
-
2005-12-22 - Beschluss d. Vorstandes
-
2005-07-12 - Satzung
-
2005-06-02 - Protokoll d. Hauptversammlung
-
2005-06-02 - Protokoll