-
SAF-HOLLAND GmbH - Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB9685 ASCHAFFENBURG
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Hauptstraße 26
- 63856 Bessenbach Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach DE
Management
- Managing Directors
- André Philipp (Geschaeftsfuehrer)
- Alexander Geis (Geschaeftsfuehrer)
- Christoph Günter (Geschaeftsfuehrer)
- Company secretaries
- Jörg Andreas Wahl (Prokura)
- Alfred Himml (Prokura)
- Alf Armin Hospes (Prokura)
- Alexandre Sébastien Charpiot (Prokura)
- Thomas Grimm (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 2006-06-26
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 2006-06-26 17 years
Ownership
- Share Capital
- 25.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- Court
- DE/Aschaffenburg
- Previous Names
- SAF-HOLLAND GROUP GmbH
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 529900NHBKBLLVU9QB02
- VAT Number
- DE814860766
- Website
- https://www.safholland.de/de/de/
- email address
- info@safholland.de
- Phone
- +49 60953010
- Fax
- +49 6095301200
-
SAF-HOLLAND GmbH Company Description
- SAF-HOLLAND GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB9685 ASCHAFFENBURG. Its current trading status is "live". It was registered 2006-06-26. It was previously called SAF-HOLLAND GROUP GmbH. and 5 secretaries. The managing director is André Philipp,Alexander Geis,Christoph Günter.It can be contacted at Hauptstraße 26 by phone on +49 60953010 by email at info@safholland.de by fax on +49 6095301200 on the web at https://www.safholland.de/de/de/.
Get SAF-HOLLAND GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Saf-Holland Gmbh - Hauptstraße 26, 63856 Bessenbach, Germany
- 2006-06-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2023-09-30 Modification
- Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § * Abs. * UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
-
SAF-HOLLAND GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for SAF-HOLLAND GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2022
-
2022-02-07 - Anmeldung vom 07.02.2022
-
2022-12-21 - Anmeldung vom 21.12.2022
-
2022-06-22 - Anmeldung vom 22.06.2022
-
2022-05-25 - Anmeldung vom 25.05.2022
-
2022-01-24 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 24.01.2022
-
2022-12-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.12.2022
-
2022-05-25 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 25.05.2022
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-07-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.07.2020
-
2020-06-24 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 24.06.2020
-
2020-06-24 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 24.06.2020
-
2020-07-08 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 08.07.2020
-
2020-09-10 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 10.09.2020
-
2020-09-10 - Anmeldung vom 10.09.2020
-
2020-09-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.09.2020
-
2020-07-08 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.07.2020
-
2020-07-22 - Anmeldung vom 22.07.2020
-
2020-09-om 24 - => Anmeldung vom 24.09.2020
-
2020-10-02 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 02.10.2020
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-09-26 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.09.2019
-
2019-03-11 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 11.03.2019
-
2019-09-26 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 26.09.2019
-
2019-03-11 - Anmeldung vom 11.03.2019
-
2019-01-07 - Anmeldung vom 07.01.2019
-
2019-03-11 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 11.03.2019
-
2019-10-22 - Anmeldung vom 22.10.2019
-
2019-09-19 - Anmeldung vom 19.09.2019
-
2019-07-05 - Anmeldung vom 05.07.2019
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-11-07 - Anmeldung vom 07.11.2018
-
2018-09-06 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 06.09.2018
-
2018-02-01 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 01.02.2018
-
2018-02-28 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 28.02.2018
-
2018-03-09 - Anmeldung vom 09.03.2018
-
2018-09-06 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 06.09.2018
-
2018-12-06 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 06.12.2018
-
2018-09-13 - Anmeldung vom 13.09.2018
-
2018-12-06 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 06.12.2018
-
2018-02-01 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 01.02.2018
-
2018-02-28 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 28.02.2018
-
2018-09-06 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 06.09.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-03-15 - Anmeldung vom 15.03.2017
-
2017-03-15 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 15.03.2017
-
2017-03-15 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 15.03.2017
-
2017-03-08 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 08.03.2017
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-11-24 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 24.11.2016
-
2016-11-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.11.2016
-
2016-11-24 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 24.11.2016
-
2016-06-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.06.2016
-
2016-11-24 - Anmeldung vom 24.11.2016
-
2016-06-08 - Anmeldung vom 08.06.2016
-
2016-03-07 - Anmeldung vom 07.03.2016
-
2016-01-15 - Anmeldung vom 15.01.2016
-
2016-11-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.11.2016
-
2016-12-19 - Anmeldung vom 19.12.2016
-
2016-06-08 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 08.06.2016
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-05-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.05.2015
-
2015-12-28 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 28.12.2015
-
2015-12-28 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 28.12.2015
-
2015-07-16 - Anmeldung vom 16.07.2015
-
2015-08-07 - Anmeldung vom 07.08.2015
-
2015-05-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.05.2015
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-03-21 - Anmeldung vom 21.03.2014
-
2014-03-26 - Anmeldung vom 26.03.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-07-29 - Anmeldung vom 29.07.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-10-08 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 08.10.2012
-
2012-01-25 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 25.01.2012
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-11-24 - Anmeldung vom 24.11.2011
-
2011-11-16 - Anmeldung vom 16.11.2011
-
2011-08-11 - Anmeldung vom 11.08.2011
-
2011-08-09 - Anmeldung vom 09.08.2011
-
2011-06-30 - Anmeldung vom 30.06.2011
-
2011-08-12 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 12.08.2011
-
2011-01-11 - Anmeldung vom 11.01.2011
-
2011-08-04 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 04.08.2011
-
2011-08-04 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 04.08.2011
-
2011-07-29 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 29.07.2011
-
2011-01-11 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 11.01.2011
-
2011-06-30 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 30.06.2011
-
2011-08-04 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 04.08.2011
-
2011-11-08 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 08.11.2011
-
2011-08-09 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 09.08.2011
-
2011-08-04 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 04.08.2011
-
2011-11-08 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 08.11.2011
-
2011-07-29 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 29.07.2011
-
2011-11-18 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 18.11.2011
-
2011-01-11 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 11.01.2011
-
2011-06-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.06.2011
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-01-11 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 11.01.2010
-
2010-01-11 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 11.01.2010
-
2010-01-07 - Anmeldung vom 07.01.2010
-
2010-12-31 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 31.12.2010
-
2010-12-31 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 31.12.2010
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-01-23 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 23.01.2009
-
2009-01-23 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 23.01.2009
-
2009-02-11 - Übersetzung vom 11.02.2009
-
2009-02-02 - Anmeldung vom 02.02.2009
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-10-07 - Anmeldung vom 07.10.2008
-
2008-10-02 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 02.10.2008
-
2008-10-02 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 02.10.2008
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-07-26 - Anmeldung vom 26.07.2007
-
2007-10-22 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 22.10.2007
-
2007-06-29 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 29.06.2007
-
2007-06-29 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 29.06.2007
-
2007-10-22 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 22.10.2007
keyboard_arrow_right 2006
-
2006-12-12 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 12.12.2006
-
2006-12-12 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 12.12.2006
-
2006-12-12 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 12.12.2006
-
2006-12-18 - Anmeldung vom 18.12.2006